UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Anderson Design & Build LTD

Adresse
Springfield Lodge
Colchester Road
Springfield
Chelmsford
CM2 5PW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
1. September 2020
FB Name Anderson Design & Build Limited
Firmenbuch-Nummer 04691622 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 3. April 2022
Branche (ÖNACE)68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Anderson Design & Build Limited | Anderson Group
  • Atta Cephalotes Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Anderson Development Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 14763895 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Anderson Construction Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 02605194 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Anderson, Mark Jonathon Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Significant influence or control as firm
  • gb-flag GB Hard Hat Construction Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 14763958 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Short, Andrew Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 30.06.2016 Geburtsdatum: 05.1956 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Aldridge, Mark Justin Colchester Road Springfield, Chelmsford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2023 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Anderson, Mark Jonathon London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2003 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jay, Andrew John Colchester Road Springfield, Chelmsford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2019 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Short, Andrew Christopher Woking, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2009 Löschung: 12.02.2024 Rolle: Secretary Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Chilton Place (Sudbury) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2020 Companies House Nummer: 12685023 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Quarry (Erith) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2017 Companies House Nummer: 10986303 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors