UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Hard HAT Construction Group Limited

Adresse
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford
CM2 5PW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
28. April 2024
Firmenbuch-Nummer 14763958 Companies House Eintrag ansehen
JahresabschlussNO ACCOUNTS FILED

Branche (ÖNACE)64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Hard Hat Trustee Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Companies House Nummer: 14857156 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Anderson, Mark Jonathon Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2023 Löschung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 09.1961 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Aldridge, Mark Justin Springfield, Chelmsford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2023 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Anderson, Mark Jonathon Springfield, Chelmsford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2023 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jay, Andrew John Springfield, Chelmsford, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2023 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Short, Andrew Christopher Springfield, Chelmsford, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2023 Löschung: 12.02.2024 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Short, Andrew Christopher Springfield, Chelmsford, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.03.2023 Löschung: 12.02.2024 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Anderson Construction LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 02605194 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag 3R Remediation Regeneration Renewables Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 04001594 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Anderson Design & Build LTD Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 04691622 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Anderson Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 06365706 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Anderson Group Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 05166622 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Anderson Group Services LTD Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 03930713 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Anderson O&U Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 11102447 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Constable Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 03943413 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Ripley Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 04841522 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Tawney Facilities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 03.04.2023 Companies House Nummer: 03123663 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors