UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Paypoint PLC

Adresse
1 The Boulevard
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1EL
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 03581541 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Officers (15)

Quelle: Companies House
Harding, David Robert Shire Park, Welwyn Garden City Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2023 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
gb-flag GB Indigo Corporate Secretary Limited Rectory Grove, Leigh-On-Sea, England, SS9 2HL Status: Aktiv Eintragung: 29.12.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 13253973
Kerr, Giles Francis Bertram Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2015 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Shapland, Rosemary Jean Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2020 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Sharma, Rakesh Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2017 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Tu, Thi Nhuoc Lan Shire Park, Welwyn Garden City Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2024 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
Wiles, Nicholas Winston Braid Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2009 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
Wishart, Ben Shire Park, Welwyn Garden City, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Chief Information Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: British
Barr, Gillian Carole Shire Park, Welwyn Garden City Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2015 Löschung: 01.08.2024 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
Bull, Ian Alan Haddenham Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.1998 Löschung: 20.07.2004 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Dale, Alan Christopher Shire Park, Welwyn Garden City Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2020 Löschung: 07.09.2023 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Kentleton, Rachel Elizabeth Shire Park, Welwyn Garden City Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2017 Löschung: 30.06.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Mclelland, Brian Shire Park, Welwyn Garden City Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2022 Löschung: 29.12.2023 Rolle: Secretary
Parsons, Guy Paul Cuthbert Shire Park, Welwyn Garden City Status: Inaktiv Eintragung: 23.03.2023 Löschung: 01.08.2024 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
Rowley, Stephen Paul, Mr. Shire Park, Welwyn Garden City Status: Inaktiv Eintragung: 16.09.2008 Löschung: 04.02.2016 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

gb-flag Appreciate Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Companies House Nummer: 01711939 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Collect + Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2016 Companies House Nummer: 10520701 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Handepay LTD. Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Companies House Nummer: 05504126 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB I-Movo Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2020 Companies House Nummer: 04877651 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Merchant Rentals LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Companies House Nummer: 04443310 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Paypoint Collections Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03581551 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Paypoint Network LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02973115 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Paypoint Payment Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08633289 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Paypoint Retail Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04476269 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Adaptis Solutions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.03.2017 Companies House Nummer: 05106124 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more