UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Community Energy Twemlows C.I.C

Adresse
1-45 Durham Street
London
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
FB Name Community Energy Twemlows C.I.C.
FB Adresse C/O Sharenergy, The Pump House
London
SY1 2DP
Firmenbuch-Nummer 09644669 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)35110 - Elektrizitätserzeugung
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Twemlows Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Companies House Nummer: 10490066 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Belle Isle Farms Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.04.2018 Companies House Nummer: 06476071 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Ib Vogt Gmbh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.04.2018 Companies House Nummer: Hrb 86173 B Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Vogt, Dagmar Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.04.2018 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Betts, Howard John Coton Hill, Shrewsbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Green, David Stephen Coton Hill, Shrewsbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Community Energy Development Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Saunders, Robert Thomas Couper Coton Hill, Shrewsbury, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2023 Beschäftigung: Driver & Driving Instructor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Humphrey, Craig Andrew 1-45 Durham Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2019 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: New Zealander
    Mansfield, James Lawrence 1-45 Durham Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2020 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Sarvarian, Andre 1-45 Durham Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2019 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Speak, Richard John 1-45 Durham Street, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.04.2019 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British