UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Mick George LTD

Adresse
6 Lancaster Way
Ermine Business Park
Huntingdon
PE29 6XU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
13. Oktober 2019
FB Name Mick George Limited
FB Adresse Second Floor, Arena Court
Huntingdon
SL6 8QZ
Firmenbuch-Nummer 02417831 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)08110 Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle
38320 - Rückgewinnung sortierter Werkstoffe
43120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Mick George (Haulage) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Hanson Quarry Products Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Companies House Nummer: 00300002 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • George, Michael Eric Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (14)

    Quelle: Companies House
    George, Michael Alexander Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2011 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Contracts Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    George, Michael Eric Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1991 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Haulage Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gretton, Edward Alexander Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Quilez Somolinos, Alfredo Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish
    Rogers, Wendy Fiona Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Rolle: Secretary
    Stump, Jonathan Paul Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2005 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Whitelaw, James Stuart Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Willis, Simon Lloyd Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Chief Executive, Heidelberg Materials Uk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Costello, Stuart Andrew Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Farrell, Karen Ann Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2019 Löschung: 03.05.2024 Rolle: Secretary
    Farrell, Karen Ann Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gossage, Joseph Andrew Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Logistics And Compliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Johnson, Neil Graham Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2008 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Technical Waste Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ward, Ryan Lee Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Sales Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Drbs East LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 04325783 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Mick George Concrete Limited | Mick George Concrete Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Companies House Nummer: 08240961 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Mick George EBT Trustee Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Companies House Nummer: 13650351 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mick George Earthworks Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 09618109 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mick George Mepal Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 03398434 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mick George Recycling Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Companies House Nummer: 10611481 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Connect365 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2017 Löschung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 10746452 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Fengate Land Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.03.2021 Löschung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 13183389 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB MG Mini Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2016 Löschung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 08824607 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB MG Vehicle Leasing Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.05.2017 Löschung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 10761929 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors