UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Beacon LIP Limited

Adresse
99 Leigh Road
Eastleigh
Hampshire
SO50 9DR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
2. Mai 2019
FB Adresse Baird House Seebeck Place
Fareham
MK5 8FR
Firmenbuch-Nummer 10035139 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Fts Recovery Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Companies House Nummer: 13951545 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Brown, Cheryl Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Fox, Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2020 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pretty, James Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.01.2021 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Coleman, Alan Brian Knowlhill, Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Licensed Insolvency Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Piacquadio, Marco Knowlhill, Milton Keynes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Stelaris Directors Ltd Farringdon, London, England, EC1M 6AW Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 15349718
    Brown, Cheryl Ann East Street, Titchfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2016 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Insolvency Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fox, Matthew East Street, Titchfield, Fareham, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2019 Löschung: 30.08.2024 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Vine, Philip Martin Solent Business Park, Whiteley, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.08.2023 Löschung: 28.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British