UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Threadneedle Curtis Limited

Adresse
78 Cannon Street
London
EC4N 6AG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
14. April 2020
Firmenbuch-Nummer 04330721 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • MAG Investment Assets Limited
  • MAG Investment Assets PLC
  • The Manchester Airport Group PLC
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Threadneedle Asset Management Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 03554212 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Voting rights 75 to 100 percent as firm
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • gb-flag GB Threadneedle Property Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 01497014 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Manchester Airport Group Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.08.2020 Companies House Nummer: 08338555 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Karim, Shazna London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2022 Rolle: Secretary
    Lauder, Stephen London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Rigg, James Mark Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Stone, Peter William London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Vullo, Giuseppe London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Weeks, Thomas William London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2020 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Cornish, Charles Thomas Olympic House Manchester Airport, Manchester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2010 Löschung: 07.08.2020 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag Parsonage Farm (Stansted) LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2024 Companies House Nummer: 06257764 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Manchester Airport Group Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.03.2018 Companies House Nummer: 08338561 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Manchester Airport Group Funding PLC Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.03.2018 Companies House Nummer: 08826541 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors