UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Geschäftsname

Lifearc

Handelsname MRC Technology
Adresse
7-12 Tavistock Square
London
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
2. August 2017
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
26. Jänner 2018
FB Name Lifearc
FB Adresse 7th Floor
London
WC1H 9LT
Firmenbuch-Nummer 02698321 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)72110 - Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Medical Research Council Technology | MRC Technology
  • Medical Research Council Technology
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Officers (15)

    Quelle: Companies House
    Cooper, Teresa Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Retired Deloitte Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British
    Davidson, Rachael Jennifer Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Rolle: Secretary
    Gilham, Ian David Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lee, Melanie Georgina Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 07.1958 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Maikovsky, Stephane Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Makarem, Rima Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Board Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mistry, Sameer Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2023 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Morgan, Daniel John Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2017 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Nicholson, Ian James Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pisani, Joanne Patra London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2020 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Strategic Advisor And Non Executive Dire Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Robb, Lynne Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2020 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Non-Exec Director Of Medicine Discovery Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wallcraft, Susan Jean 7th Floor, Lynton House 7-12 Tavistock Square, London, WC1H 9LT Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Zahn, David Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2019 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,American
    Bliss, Edward Robert Clegg Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2015 Löschung: 01.09.2023 Rolle: Secretary
    Lee, Melanie Georgina, Dr Lynton House 7-12 Tavistock Square, London Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2019 Löschung: 01.10.2023 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag Gyreox Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2020 Companies House Nummer: 12006578 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Ikarovec Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Companies House Nummer: 11504964 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Lifearc Innovations Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2017 Companies House Nummer: 11093411 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag RQ Biotechnology Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Companies House Nummer: 13293828 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag RQ Biotechnology Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2023 Companies House Nummer: 13293828 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Aviadobio LTD Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2020 Löschung: 03.12.2021 Companies House Nummer: 12373955 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control