UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Continental Product Supply Limited

Adresse
The Courtyard
Sky House
Raans Road
Amersham
HP6 6JQ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name Continental Product Supply LTD
Firmenbuch-Nummer 03554396 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Continental Supply Company LTD
  • Dexter Corporate Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

    Quelle: Companies House
    Davis, Gary Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Dbp Zenith Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.02.2021 Companies House Nummer: 12775396 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Iq Glass Group Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2021 Löschung: 18.02.2021 Companies House Nummer: 12775071 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Iq Glass Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2019 Löschung: 03.02.2021 Companies House Nummer: 11775014 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Murray, Keith Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2018 Löschung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Thompson, Graham John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.04.2019 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Beaumont, Richard Terence Amersham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2021 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Davis, Gary John Amersham, Bucks Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2006 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Piekarewicz, Michal Amersham, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2021 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish