UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

F.G. Curtis Limited

Adresse
Unit 8 Gatton Pk Bus Ctr
Wells Place
Merstham
Redhill Surrey
RH1 3DR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 00367479 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)17120 - Herstellung von Papier, Karton und Pappe
18129 - Drucken a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • F G Curtis PLC
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Appleseed Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Companies House Nummer: 09250828 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Curtis, Jennifer Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.08.2017 Geburtsdatum: 03.1946 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Curtis, John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 11.1942 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Agnew, James Douglas Gatton Park Business Centre, Wells Place, Merstham, Redhill, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Brade, Jeremy James Gatton Park Business Centre, Wells Place, Merstham, Redhill, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Harford, Gerard Patrick Gatton Park Business Centre, Wells Place, Merstham, Redhill, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Stokes, Mark Bryan Gatton Park Business Centre, Wells Place, Merstham, Redhill, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Williams, James Winston Gatton Park Business Centre, Wells Place, Merstham, Redhill, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2002 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Curtis, Peter Ben Redhill, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.08.1991 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Curtis, Peter Ben Redhill, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.1997 Löschung: 27.10.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Secretary Nationalität: British
    Mallett, Steven John Redhill, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.08.2002 Löschung: 03.04.2024 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag 3D Creative Packaging LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07161440 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Voting rights 75 to 100 percent as firm

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Altype Engineers (Raynes Park) LTD212 Durnsford Rd, Wimbledon, London, SW19 8DR