UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Altaras International Worcester Limited

Adresse
Great Western Business Park
Worcester
WR4 9PT
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
10. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
18. Juni 2018
FB Adresse Morvern House Ormonde Drive
Ripley
DE5 8LE
Firmenbuch-Nummer 07877065 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)28990 - Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Deltacam International Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Tarpey-Harris Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.12.2016 Companies House Nummer: 00958369 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • France, Neil John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2016 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Garner Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.12.2016 Löschung: 31.12.2016 Companies House Nummer: 08403462 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Simpson, Ian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.12.2016 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Tarpey-Harris Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.2016 Löschung: 31.12.2016 Companies House Nummer: 00958369 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (10)

    Quelle: Companies House
    Freimund, Jorg Helmut Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German
    Lewis, Philip Andrew Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2023 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lewis, Phillip Andrew, Dr Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcgreevy, Paul Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2019 Rolle: Secretary
    Simpson, Ian Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2012 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Steen, Jason Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Steffens, Klaus Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Geburtsdatum: 02.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German
    Urch, Mark Denby, Ripley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    France, Neil John Denby, Ripley, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.02.2012 Löschung: 02.02.2024 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Holland, Mark Denby, Ripley, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2019 Löschung: 06.03.2023 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British