UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Washco Limited

Adresse
Unit 11
Arnhem Road
Bone Lane
Newbury
RG14 5RU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
22. Februar 2019
FB Adresse C/O Hughes Units 1-5 Warwick Court Ellough Industrial Estate
Lowestoft
NR34 7FD
Firmenbuch-Nummer 00231369 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • James Armstrong and CO LTD
  • James Armstrong and Company Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Hughes Electrical Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Companies House Nummer: 00406069 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hughes Electrical Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2018 Löschung: 25.02.2019 Companies House Nummer: 00406069 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Hughes, Robert John Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2018 Löschung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB James Armstrong Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.02.2019 Löschung: 31.03.2022 Companies House Nummer: 07866098 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB James Armstrong Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2018 Companies House Nummer: 07866098 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Holmes, James Robert Glenn Gorleston Road, Lowestoft, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hosking, Peter Anthony Ellough, Beccles, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hughes, Robert John Ellough, Beccles, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sand, Michael Ellough, Beccles, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: Danish
    Thornton, Christopher William Gorleston Road, Lowestoft, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Thornton, Christopher William Ellough, Beccles, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2018 Rolle: Secretary
    Whitehead, David Nigel Ellough, Beccles, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Chisnall, Paul Terence Gorleston Road, Lowestoft, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.01.2018 Löschung: 28.02.2019 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Goodman-Sparks Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Companies House Nummer: 14097750 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Solent Laundry Solutions (Holding) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Companies House Nummer: 11487513 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Armstrong Rentals LTDAmpere Road, Newbury, Berks, RG14 2AE