UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Pbsl Group Limited

Adresse
1B Altbarn Road
Hawkins Road
Colchester
Essex
CO2 8LG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
17. April 2018
Firmenbuch-Nummer 06612338 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Professional Building Supplies LTD
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Pbsl Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Companies House Nummer: 13214206 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Evans, Colin Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Evans, Sarah Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Priestley, Spencer James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 12.1978 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Brown, Steven Ian Hawkins Road, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bulearca, Marina Suzana Hawkins Road, Colchester Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2019 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian,British
    Dixon, Grant Derrick Hawkins Road, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Easteal, Christopher James Hawkins Road, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2023 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Heygate, Samuel Thomas Roger Hawkins Road, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2022 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Orchard, Marcus Timothy Jackson Hawkins Road, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Perry, Duncan Hawkins Road, Colchester Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2019 Löschung: 31.12.2022 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Bifoldsales Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 14226905 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Bolts Online Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 14226986 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cablestore Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 14227011 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Composite Sales Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 14226930 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Danlett Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2019 Companies House Nummer: 06391718 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Drainage Sales LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Companies House Nummer: 07951071 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Gutter Supplies LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Companies House Nummer: 06743015 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB PVC Cladding Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Companies House Nummer: 08287480 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Professional Building Supplies Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2017 Companies House Nummer: 10558843 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Soakaways Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2022 Companies House Nummer: 14226945 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors