UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Cera Care Limited

Adresse
Crown House
Stephenson Road
Severalls Industrial Park
Colchester
CO4 9QR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
24. August 2022
Firmenbuch-Nummer 09874278 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)86102 - Krankenhäuser
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Golden ERA Club LTD
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    Sacha, Marek Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.03.2018 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Significant influence or control as firm
  • Officers (18)

    Quelle: Companies House
    Ashley, Matthew Edward Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Brode, Andrew Stephen Chalfont St. Peter, Buckinghamshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2019 Geburtsdatum: 09.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Gallwey, Dayrell Shane London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2021 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Jain, Ankur Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 05.06.2020 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Landucci-Harmey, James Conor Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2023 Rolle: Secretary
    Maruthappu, Mahiben Kensington, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2016 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Maruthappu, Mahiben, Dr Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2016 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sabe, Jordi Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2024 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish
    Sacha, Marek Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2015 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Czech
    Sands, Peter Alexander Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2017 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Senior Fellow Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sohler, Matthias Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German
    Aciman, Igal Kensington, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.05.2019 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Turkish
    Gallwey, Dayrell Shane, Mr. London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2021 Löschung: 01.06.2024 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Jennings, Marcus Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.05.2023 Löschung: 01.06.2024 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    King, Malcolm Anthony Wallace, Dr Kensington, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2018 Löschung: 05.06.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,South African
    KlÖss-Braekler, Susanne Kensington, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2021 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Board Member & Senior Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German
    Mazzi, Christian Paolo London, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.04.2021 Löschung: 01.06.2024 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian
    Seidel, Gerrit Rene, Dr Severalls Industrial Park, Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2023 Löschung: 01.06.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Cera Care Operations Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2020 Companies House Nummer: 12397791 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Advanced Community Healthcare Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2023 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 07542839 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Care Quality Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2023 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 11696513 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag Cera Care Technology Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2021 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 13807260 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cyprian Care LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2019 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 05996908 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Gemcare South West Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.07.2020 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 08611694 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Nobilis Care North Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2022 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 12214004 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Nobilis Care West Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2022 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 05100079 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Premier Care Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2023 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 05213770 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Premier Care Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2023 Löschung: 24.02.2023 Companies House Nummer: 05213770 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control