UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

MTD Coln Industrial LTD

Adresse
Clive House
Old Brewery Mews
Hampstead
London
NW3 1PZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name MTD Coln Industrial Limited
FB Adresse 12th Floor Aldgate Tower
London
E1W 9US
Firmenbuch-Nummer 06941101 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Property Auction Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

    Quelle: Companies House
    Baker, Michael Terence Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Mendelsohn, Jonathan Neil Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pears, Daniela Claire Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2018 Geburtsdatum: 05.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pears, David Alan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pears, Mark Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1962 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pears, Trevor Steven Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Rowley, Nigel Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Shaw, Barry Michael Howard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Bennett, William Frederick London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2013 Rolle: Secretary
    Pears, David Alan Hampstead, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2011 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pears, Mark Andrew Hampstead, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2011 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pears, Trevor Steven London Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2009 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pears, Trevor Steven, Sir London Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2009 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Wpg Registrars Limited Aldgate Tower, 2 Leman Street, London, United Kingdom, E1W 9US Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2011 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 05513520
    Wpg Registrars Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2011 Rolle: Director

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

    gb-flag GB Camberley Business Centre Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2018 Companies House Nummer: 05456147 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Camberley Business Centre 2 Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.07.2018 Löschung: 08.11.2021 Companies House Nummer: 07846443 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Cosgrove WAY Estate Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2019 Löschung: 22.01.2021 Companies House Nummer: 12132486 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Stafford Park 15 Management Company LTD Status: Inaktiv Eintragung: 24.02.2017 Löschung: 25.09.2018 Companies House Nummer: 10637944 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Windover Court Estate Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2018 Löschung: 28.02.2020 Companies House Nummer: 11711044 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - 75% or more