UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Mick George LTD

Adresse
6 Lancaster Way
Ermine Business Park
Huntingdon
Cambridgeshire
PE29 6XU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
24. April 2018
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
1. November 2019
FB Name Mick George Limited
FB Adresse Second Floor, Arena Court
Huntingdon
SL6 8QZ
Firmenbuch-Nummer 02417831 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)08110 Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle
38320 - Rückgewinnung sortierter Werkstoffe
43120 - Vorbereitende Baustellenarbeiten
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Mick George (Haulage) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Hanson Quarry Products Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Companies House Nummer: 00300002 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • George, Michael Eric Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (14)

    Quelle: Companies House
    George, Michael Alexander Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2011 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Contracts Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    George, Michael Eric Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1991 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Haulage Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gretton, Edward Alexander Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Quilez Somolinos, Alfredo Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish
    Rogers, Wendy Fiona Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Rolle: Secretary
    Stump, Jonathan Paul Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2005 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Whitelaw, James Stuart Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Willis, Simon Lloyd Maidenhead, England Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2024 Beschäftigung: Chief Executive, Heidelberg Materials Uk Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Costello, Stuart Andrew Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Farrell, Karen Ann Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2019 Löschung: 03.05.2024 Rolle: Secretary
    Farrell, Karen Ann Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 06.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gossage, Joseph Andrew Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Logistics And Compliance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Johnson, Neil Graham Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2008 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Technical Waste Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ward, Ryan Lee Maidenhead, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.09.2019 Löschung: 03.05.2024 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Sales Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Drbs East LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 04325783 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Mick George Concrete Limited | Mick George Concrete Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Companies House Nummer: 08240961 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Mick George EBT Trustee Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Companies House Nummer: 13650351 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mick George Earthworks Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Companies House Nummer: 09618109 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mick George Mepal Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 03398434 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mick George Recycling Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Companies House Nummer: 10611481 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Connect365 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2017 Löschung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 10746452 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Fengate Land Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.03.2021 Löschung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 13183389 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB MG Mini Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.12.2016 Löschung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 08824607 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB MG Vehicle Leasing Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.05.2017 Löschung: 09.12.2022 Companies House Nummer: 10761929 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors