UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

HCC Properties Limited

Adresse
The Inspire
Hornbeam Square West
Harrogate
HG2 8PA
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 05946999 Companies House Eintrag ansehen
FB StatusDissolved
Gründungsdatum26. September 2006
JahresabschlussFULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)74990 - Non-trading company
Vorherige Namen
  • Trushelfco (NO.3246) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Principal Hayley Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 04977436 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Hcc Group Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 05971189 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • Officers (2)

    Quelle: Companies House
    Burrell, James Alexander Harrogate, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2014 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Troy, Anthony Gerrard Darley Road, Bristwith, Harrogate, North Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2007 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

    gb-flag GB Beaumont House Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 05971173 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cranage Hall Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 05940107 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Sedgebrook Hall Properties Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2017 Companies House Nummer: 05944123 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag The Derbyshire Hotel Derby Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.10.2017 Companies House Nummer: 06291448 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB The ST David's Hotel Cardiff Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.07.2018 Companies House Nummer: 03299012 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag The ST Johns Hotel Solihull Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2017 Companies House Nummer: 06311941 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Venice Spareco 2 Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 05947281 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control