UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Dcukfm Holdings Limited

Adresse
Compass House
Manor Royal
Crawley
RH10 9PY
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 12519609 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Notsallow 900 Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Rentokil Initial Uk Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Companies House Nummer: 00301044 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Jones, Nigel John Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Jones, Sandra Kim Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Gordon, James Robert Anthony Crawley, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2024 Rolle: Secretary
    Harris, Grace Elizabeth Crawley, England Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Wood, Phillip Paul Crawley, England Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Bone, Darren Lee Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Carraher, Jamie Andrew Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Health And Safety Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Davies, Paul Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Technical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jones, Nigel John Welwyn Garden City, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jones, Nigel John Welwyn Garden City, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Rolle: Secretary
    Stottor, Mark Vernon Crawley, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2020 Löschung: 05.03.2024 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag Ductclean (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2020 Companies House Nummer: 03639301 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Waterized Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2020 Companies House Nummer: 12995251 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors