UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

ONE Point Telecom LTD

Adresse
9 Sundial Court
Tolworth Rise
Tolworth
KT5 9RN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name ONE Point Telecom Limited
FB Adresse 5 Hatfields
London
SE1 9PG
Firmenbuch-Nummer 04994962 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussdormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)61900 - Sonstige Telekommunikation
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Fluidone Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Fluidone Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.12.2016 Löschung: 11.09.2017 Companies House Nummer: 05296759 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Mcelligott, Ben Michael David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.12.2016 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB One Point Communications Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 27.02.2019 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rigby Technology Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.02.2019 Companies House Nummer: 09787794 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Hastings, Roy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2021 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Horton, Russell Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lynch, Philip Brendan London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2022 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Chief Revenue Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Rogers, Christopher James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2019 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Taylor, John Paul Stratford-Upon-Avon, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2018 Löschung: 27.02.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag GB ONE Point Communications Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04128817 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors