UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

D M Energy LTD

Adresse
62 Swinton Avenue
Baillieston
Glasgow
G69 6LY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
6. Mai 2017
FB Name DM Energy Limited
FB Adresse 4th Floor 24 Old Bond Street
Accrington
W1S 4AW
Firmenbuch-Nummer 12150130 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)43210 - Elektroinstallation
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Avonside Energy Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Companies House Nummer: 12565118 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Ashley, Dana Michelle Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2020 Löschung: 28.08.2021 Geburtsdatum: 02.1974 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Pickup, Mathew Mark Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2019 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Seddon, Duncan Matthew Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2019 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Cossey Cosec Services Limited 24 Old Bond Street, Mayfair, London, United Kingdom, W1S 4AW Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2025 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 14344691
    Rumble, William John Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Thompson, Richard John Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB W7s Directors Limited 24 Old Bond Street, Mayfair, London, United Kingdom, W1S 4AW Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 14647839
    Waller, Graham Mayfair, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pickup, Mathew Mark Accrington, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2019 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Seddon, Duncan Matthew Accrington, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2019 Löschung: 18.10.2024 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British