UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Crayfern Homes LTD

Adresse
Victoria House
14 St Johns Road
Hedge End
SO30 4AB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name Elivia Homes (Southern) Limited
FB Adresse Apollo House, Mercury Park Wycombe Lane
High Wycombe
HP10 0HH
Firmenbuch-Nummer 02703219 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)41202 - Bau von Gebäuden
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Elivia Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Companies House Nummer: 05011077 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Mussell, David Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 12.1947 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Valentine, Neil Leigh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 08.1951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Brown, Iain Mitchell Hedge End, Southampton, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Chiles, Christopher Hedge End, Southampton, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Page, Lewis James Wooburn Green, High Wycombe, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2017 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wawman, Kevin Anthony Wooburn Green, High Wycombe, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2008 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Land Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Curry, John Wooburn Green, High Wycombe, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2012 Löschung: 12.10.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Construction Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Page, Lewis Wooburn Green, High Wycombe, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2015 Löschung: 12.10.2023 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Court Laurels Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Companies House Nummer: 06835001 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hawkins Field Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2022 Companies House Nummer: 14140196 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Netley Grange Resident Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Companies House Nummer: 14785269 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Saint Georges Park (Barnham) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2023 Companies House Nummer: 14958867 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Weald Place (Worthing) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2017 Companies House Nummer: 11118472 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Arrolbeam Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.06.2019 Löschung: 05.07.2022 Companies House Nummer: 09333687 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Chesham Place Residents Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.11.2016 Löschung: 26.03.2019 Companies House Nummer: 10460104 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Gosden Green (Southbourne) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2016 Löschung: 26.10.2018 Companies House Nummer: 10265215 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Magnolia Walk Residents Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2018 Löschung: 31.07.2023 Companies House Nummer: 11516109 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Spires (Yapton) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2020 Löschung: 15.12.2021 Companies House Nummer: 12392620 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors