UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Excellerate Services UK Limited

Adresse
The Old Pump Works
Great Warley Street
Great Warley
Brentwood
CM13 3JR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
18. August 2020
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
16. Februar 2021
FB Adresse 65 Leonard Street
London
EC2A 4QS
Firmenbuch-Nummer 02770135 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)81210 - Allgemeine Gebäudereinigung
81221 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
81299 - Reinigung a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Templewood Security Services Limited
  • LCC Support Services Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Excellerate Services Holdings Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2021 Companies House Nummer: 04998433 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Excellerate Services Holdings Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2021 Löschung: 22.02.2021 Companies House Nummer: 04998433 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lcc Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.02.2021 Löschung: 22.02.2021 Companies House Nummer: 07178643 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lcc Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 22.02.2021 Companies House Nummer: 07178643 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Templewood Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2018 Löschung: 31.05.2018 Companies House Nummer: 04998433 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Vincent, Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 08.1948 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Hulley, Gordon George Dunkeld West, Randburg, Johannesburg, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Group Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British
    Laird, Lisa Helen Shoreditch, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2023 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Phipps, Clinton James Dunkeld West, Randburg, Johannesburg, Gauteng Province, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Chief Operations Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African
    Soning, Harvey Murray St Johns Wood, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2018 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Venter, Johan Andrew Shoreditch, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Wilson, Christine Ann Chelmer Village, Chelmsford Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.1997 Löschung: 24.03.2010 Beschäftigung: Client Services Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wilson, Christine Ann Chelmer Village, Chelmsford Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.1997 Löschung: 01.12.2005 Beschäftigung: Client Servicesl Director Rolle: Secretary Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

    gb-flag GB Contract Cleaning and Maintenance Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2020 Companies House Nummer: 03305205 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mgdg Property UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2023 Companies House Nummer: 14536006 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Pest Free Products LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06992863 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Veridian Data Solutions UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2024 Companies House Nummer: 15700971 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%