UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Groundsure Limited

Adresse
Nile House
Nile Street
Brighton
BN1 1HW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
28. Februar 2021
Firmenbuch-Nummer 03421028 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)58190 - Sonstiges Verlagswesen (ohne Software)
63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
70229 - Unternehmensberatung
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Ati Uk Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Companies House Nummer: 13130846 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Ascential Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2020 Löschung: 20.01.2021 Companies House Nummer: 00435820 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Bep Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.12.2020 Companies House Nummer: 08256709 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Buckle, Jonathan Mark Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Rolle: Secretary
    Hill, David Lloyd Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian
    Montagnani, Daniele Benedict Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 27.01.2021 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wood, Stephen Paul Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian
    Beurier, Stefan 1 Wilder Walk, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2016 Löschung: 10.12.2020 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French
    Gradden, Amanda Jane 1 Wilder Walk, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.01.2013 Löschung: 20.01.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hunter, Alexander Dounie London Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2001 Löschung: 08.06.2007 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Painter, Duncan Anthony 1 Wilder Walk, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2011 Löschung: 20.01.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag Conveyancing Information Executive Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Companies House Nummer: 12385597 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Cornwall Mining Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Companies House Nummer: 01381067 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • gb-flag Cornwall Mining Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2020 Companies House Nummer: 01381067 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors as firm