UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Tara Developments Limited

Adresse
1A Pool Road
Burntwood
Staffs
WS7 3QW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse St Joseph's House High Street
Burntwood
WS7 3XG
Firmenbuch-Nummer 01946080 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
Crabtree, John Rawcliffe Avery Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 08.1949 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Significant influence or control as trust
  • Davenport, Ivor Stewart Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 04.1957 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Significant influence or control as trust
  • Holder, Michael David Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Significant influence or control as trust
  • Sweeney, Mary Carmel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.06.2021 Geburtsdatum: 07.1939 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Sweeney, Noel Stephen Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Caudle, Julie Elizabeth Chasetown, Burntwood, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Rolle: Secretary
    Chapman, David George Chasetown, Burntwood, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2021 Geburtsdatum: 05.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Crabtree, John Rawcliffe Airey Chasetown, Burntwood, England Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Crabtree, John Rawcliffe Avery Chasetown, Burntwood, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 29.02.2016 Geburtsdatum: 08.1949 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Davenport, Ivor Stewart Chasetown, Burntwood, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2018 Geburtsdatum: 04.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Sweeney, Mary Carmel School Lane Gentleshaw, Rugeley, Staffs Status: Aktiv Eintragung: 31.12.1991 Geburtsdatum: 07.1939 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

    gb-flag GB Cameron Estates Management LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06764847 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag Keon Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Companies House Nummer: 11643845 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag SF Groundworks (Chasetown) LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Companies House Nummer: 07999220 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more