UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

South Staffordshire PLC

Adresse
Green Lane
Walsall
WS2 7PD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer 04295398 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Aquainvest Acquisitions Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 05208606 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Aquainvest Acquisitions Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 05208606 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hydriades Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2021 Löschung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 06403555 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Antolik, Peter Szymon London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2018 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Infrastructure Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Harris, Thomas Keith Walsall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2020 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Johnson, Stephen West Woodhay, Newbury, England Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2018 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Maher, Charlotte Tamsyn Walsall Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    O'Malley, Robert James Walsall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2020 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Stretton, Caroline Ann Walsall, West Midlands Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2020 Rolle: Secretary
    Ammoun, Roger Georges Canary Wharf, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2013 Löschung: 03.07.2018 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Buscombe, Toby Simon Walsall Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2022 Löschung: 15.03.2023 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian,

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

    gb-flag GB Inter-Credit International Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2020 Companies House Nummer: 01024737 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Omega RED Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 06399736 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Perco Engineering Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2020 Companies House Nummer: 03282344 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rapid Systems LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03290343 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB SSW Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2021 Companies House Nummer: 13682466 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Gateway Group of Companies Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2023 Companies House Nummer: 13985732 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Grosvenor Services Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.11.2021 Löschung: 14.03.2022 Companies House Nummer: 03621315 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB SSW Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2021 Löschung: 22.12.2021 Companies House Nummer: 13703008 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors