UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

RST Cardiff Limited

Adresse
1 Frederick Place
London
N8 8AF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
10. Mai 2025
FB Adresse Cmb Partners Uk Ltd
London
EC2A 4AA
Firmenbuch-Nummer 08897388 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusliquidation
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Rst Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Company Registration: 10719614 (England) Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rst Residential Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.07.2017 Company Registration: 06775786 (England) Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rst Securities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 01.10.2019 Company Registration: 11425181 (England) Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Blackmore, Mette London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Rolle: Secretary
    Massos, Christina Anna London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Rolle: Secretary
    Groombridge, James Michael Leslie London, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2014 Löschung: 25.03.2025 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Omirou, Melanie Jayne London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2014 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Skok, John Mirko London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2014 Löschung: 04.07.2019 Beschäftigung: Director, Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Summerskill, Romy Elizabeth London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2019 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Bookers Edge (Cusop) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Companies House Nummer: 09757700 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cotswold Village Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Companies House Nummer: 11344622 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Applestone Court (Fairford) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2022 Löschung: 06.10.2022 Companies House Nummer: 14288732 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Bonvilston Vale Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2018 Löschung: 06.12.2022 Companies House Nummer: 11327613 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Campus Buildings (Caerleon) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2022 Löschung: 01.12.2022 Companies House Nummer: 14233148 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Cotswold Village (Ashton Keynes) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2018 Löschung: 03.05.2018 Companies House Nummer: 11294474 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Manor Court (Greet) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2022 Löschung: 14.07.2023 Companies House Nummer: 14131276 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Merchants Place (Cardiff) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2020 Löschung: 29.11.2022 Companies House Nummer: 12500045 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Milton Street (Fairford) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2022 Löschung: 06.10.2022 Companies House Nummer: 14288620 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB ST James Square (Cheltenham) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2019 Löschung: 01.12.2022 Companies House Nummer: 11771957 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors