UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

RST Cardiff Limited

Adresse
1 Frederick Place
London
N8 8AF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. Mai 2016
FB Adresse 29 York Street
London
W1H 1EZ
Firmenbuch-Nummer 08897388 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Rst Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Companies House Nummer: 10719614 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rst Residential Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.07.2017 Companies House Nummer: 06775786 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rst Securities Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 01.10.2019 Companies House Nummer: 11425181 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Blackmore, Mette London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Rolle: Secretary
    Groombridge, James Michael Leslie London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2014 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Property Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Massos, Christina Anna London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Rolle: Secretary
    Omirou, Melanie Jayne London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2014 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Skok, John Mirko London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2014 Löschung: 04.07.2019 Beschäftigung: Director, Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Summerskill, Romy Elizabeth London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2019 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Bookers Edge (Cusop) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Companies House Nummer: 09757700 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cotswold Village Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Companies House Nummer: 11344622 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Applestone Court (Fairford) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2022 Löschung: 06.10.2022 Companies House Nummer: 14288732 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Bonvilston Vale Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2018 Löschung: 06.12.2022 Companies House Nummer: 11327613 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Cotswold Village (Ashton Keynes) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2018 Löschung: 03.05.2018 Companies House Nummer: 11294474 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Headbrook (Kington) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2017 Löschung: 16.01.2019 Companies House Nummer: 11059601 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Manor Court (Greet) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.05.2022 Löschung: 14.07.2023 Companies House Nummer: 14131276 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Merchants Place (Cardiff) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2020 Löschung: 29.11.2022 Companies House Nummer: 12500045 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB ST James Square (Cheltenham) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2019 Löschung: 01.12.2022 Companies House Nummer: 11771957 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Rest (Porthcawl) Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.04.2018 Löschung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 11327482 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors