UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Franchise Brands PLC

Adresse
Ashwood Court
Springwood Close
Tytherington Business Park
Macclesfield
SK10 2XF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
31. Jänner 2019
Firmenbuch-Nummer 10281033 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Franchise Brands Worldwide LTD
  • FB Holdings PLC
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    Hemsley, Stephen Glen Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Wray, Nigel William Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 10.03.2022 Geburtsdatum: 04.1948 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Officers (14)

    Quelle: Companies House
    Bellhouse, Robin Christian Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Rolle: Secretary
    Brattesani, Andrew Vincent Guilio Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2022 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fryer, Mark Rupert Maxwell Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hemsley, Stephen Glen Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Kear, Peter John Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wray, Nigel William Totteridge Green, London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Bellhouse, Robin Christian Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Chartered Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Choudhury, Julia Rosalind Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Harris, Timothy John Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Molloy, Peter John Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2018 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Peters, Mark Andrew Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 02.10.2023 Rolle: Secretary
    Poutney, David John Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 02.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Rees, Colin David Hoo Farm Industrial Estate, Kidderminster, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2018 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sayers, Jason Charles Tytherington Business Park, Macclesfield, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.03.2022 Löschung: 02.10.2023 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Azura Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2021 Companies House Nummer: 02531777 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Chipsaway International LTD. Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Companies House Nummer: 02962763 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB FB Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2016 Companies House Nummer: 06693122 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Filta Group Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Companies House Nummer: 10095071 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Filta Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2022 Companies House Nummer: 10095071 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hydraulic Authority I Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Companies House Nummer: 11685895 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Metro ROD Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2017 Companies House Nummer: 04235803 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Metro ROD Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2017 Companies House Nummer: 04235803 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Oven Clean Domestic Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2018 Companies House Nummer: 04944186 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag WPL Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 10802100 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more