UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Hull ECO Park Limited

Adresse
Ms3 Networks Limited Owen
Owen Avenue
Hessle
East Riding Of Yor
HU13 9PD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
6. August 2018
FB Name Hull ECO Park LTD
FB Adresse Geneva Court Geneva Way
Hull
HU7 0DG
Firmenbuch-Nummer 08516732 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2023
Branche (ÖNACE)68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Eco Park Developments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08516298 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB New Technology Developments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07604443 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Sewell Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04721032 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Barnes, Joanne Louise Hull, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2017 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Davison, Simon John Hull, England Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2021 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Fielding, Gary John Priory Park, Hessle, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Laidlaw, Bruce Hugh Leads Road, Hull, East Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 05.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Tarbotton, Benjamin Kirk Ella, East Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2016 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Turner, Christopher Gerald Burnham-On-Crouch, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2016 Geburtsdatum: 12.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hales, Antony James Hessle, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2013 Löschung: 23.02.2021 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

    gb-flag GB Hull ECO Park (Infrastructure) LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2023 Companies House Nummer: 14956052 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hull ECO Park (Phase A) LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2023 Companies House Nummer: 14956056 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hull ECO Park (Phase E) LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2023 Companies House Nummer: 14956234 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hull ECO Park (Phase E) LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2023 Companies House Nummer: 14956234 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors