UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Property Consortium (Holdings) Limited

Adresse
Blackdown House
Culmhead Business Centre
Taunton
Somerset
TA3 7DY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
16. März 2018
FB Adresse Nightingale House
Taunton
TA1 3EN
Firmenbuch-Nummer 07531688 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Property Consortium (Holdings) Limited | Claims Consortium Group
  • Property Consortium (Holdings) Limited Claims Consortium Group
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    Hyams, Jeremy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Brady, Matthew Joseph Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2011 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Clark, John Matthew Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Corfield, Chris Andrew Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gladwell, Gregory Duncan Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2017 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hyams, Jeremy Culmhead, Taunton, Somerset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2011 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lambert, Heather Jane Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Group Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pugh, Owen Edward Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2023 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Smale, Robert James Taunton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.07.2019 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcgaw, Helen Diane Culmhead, Taunton Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2022 Löschung: 17.05.2024 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

    gb-flag GB Building Claims Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04709944 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Claims Consortium Adjusting Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2019 Companies House Nummer: 12084763 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Claims Consortium Training Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Companies House Nummer: 12130299 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Digital Claims Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08948101 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Motor Claim Service Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09363367 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Property Consortium Drainage Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07018620 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Property Consortium UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03164160 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Roger Rich & CO. Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2022 Companies House Nummer: 10883370 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Right to appoint and remove directors as firm