UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Repacq Investments Limited

Adresse
Building 21, First Avenue
Pensnett Trading Estate
West Midlands
DY6 7TU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
29. April 2019
FB Adresse Unit 4 Jubilee Business Park Jubilee Way
West Yorkshire
WF4 4TD
Firmenbuch-Nummer 05965249 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Prism Medical Healthcare Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2021 Companies House Nummer: 08840024 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Elcocks, David John Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2020 Löschung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Elcocks, Janet Nellie Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 03.1951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Elcocks, John Raymond Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.02.2020 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Wardley, Lisa Jane Status: Inaktiv Eintragung: 21.02.2020 Löschung: 18.01.2021 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Leek, Jason Charles Grange Moor, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mullan, Paul James Grange Moor, West Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2023 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Neale, Robert James Grange Moor, Wakefield, England Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wardley, Lisa Jane Cradley Heath, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2006 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hart, James Thomas Grange Moor, West Yorkshire, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2021 Löschung: 30.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Heaton, Dominic Mark Grange Moor, West Yorkshire, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2023 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag Repose Furniture LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03727157 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors