UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Nexarise LTD

Adresse
The Mill
1000 Great West Road
Brentford
England
TW8 9DW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
6. September 2020
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
12. August 2022
FB Adresse Ground Floor Seneca House
Blackpool
FY4 2FF
Firmenbuch-Nummer 12579906 Companies House Eintrag ansehen
FB StatusLiquidation
Gründungsdatum30. April 2020
JahresabschlussNO ACCOUNTS FILED

Branche (ÖNACE)47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
Ali, Asad Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Mukhtar, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2020 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Thomas, Liju Georgy Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 10.1982 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Mukhtar, Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2020 Löschung: 26.06.2020 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (2)

    Quelle: Companies House
    Thomas, Liju Georgy Brentford, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Ali, Asad Brentford, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2020 Löschung: 22.02.2022 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag Arise Academy LTD Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2020 Löschung: 31.01.2022 Companies House Nummer: 12817292 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Lifestyle By Nexarise LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2020 Löschung: 31.01.2022 Companies House Nummer: 12781507 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag NEX Mobile LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2020 Löschung: 31.01.2022 Companies House Nummer: 12781490 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB NEX Shield LTD Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 06.03.2023 Companies House Nummer: 12783959 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Nexarise European Services LTD Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2020 Löschung: 31.01.2022 Companies House Nummer: 12809334 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Tech By Nexarise LTD Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 31.01.2022 Companies House Nummer: 12783709 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors