UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Axil Integrated Services Limited

Adresse
14 Earlstrees Court
Earlstrees Industrial Estat
Corby
NN17 4AX
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
17. November 2019
Firmenbuch-Nummer 09204100 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen
  • Axil Integrated Services LTD | Axil IS
  • Augean Integrated Services Limited
  • Herculean Integrated Services Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Regen Devco Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Companies House Nummer: 09389144 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Augean Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.03.2018 Companies House Nummer: 05199719 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Lang, Jason Earlstrees Industrial Estate, Corby, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pigg, Edward Earlstrees Industrial Estate, Corby, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2014 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Astor, James Alexander Waldorf Earlstrees Industrial Estate, Corby, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 27.03.2025 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fryer, Mark Rupert Maxwell South Witham, Grantham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2016 Löschung: 16.03.2018 Beschäftigung: Group Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    O'Donoghue, Christopher Earlstrees Industrial Estate, Corby, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 17.10.2024 Rolle: Secretary
    O'Donoghue, Christopher John Earlstrees Industrial Estate, Corby, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 17.10.2024 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Priestley, Richard Paul Earlstrees Industrial Estate, Corby, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2018 Löschung: 27.03.2025 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag GB Envpact Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2022 Companies House Nummer: 13897063 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors