UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Iqvia LTD.

Adresse
3 Forbury Place
23 Forbury Road
Reading
RG1 3JH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
2. Juli 2018
Firmenbuch-Nummer 03022416 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
72110 - Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
73200 - Markt- und Meinungsforschung
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Quintiles Limited
  • Iqvia LTD | Iqvia LTD
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Iqvia Rds Holdings Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02703164 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Quintiles Holdings Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Berkshire, James Grant 23 Forbury Road, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Vice President, Business Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Halco Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2018 Rolle: Secretary
    gb-flag GB Jtc (uk) Limited 52 Lime Street, London, United Kingdom, EC3M 7AF Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 04301763
    Kotchie, Natalia Alexandra 23 Forbury Road, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Vice President, R & D Solutions Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American
    Randall, Kerry Louise 23 Forbury Road, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Beschäftigung: Vice President, Global Site Activation Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Sheppard, Timothy Peter 23 Forbury Road, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Turland, Kevin John 23 Forbury Road, Reading, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2014 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    gb-flag GB Halco Secretaries Limited Fleet Place, London, England, EC4M 7RD Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2018 Löschung: 21.06.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 02503744

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag Clintec International Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2018 Companies House Nummer: 03307476 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GCE Clin Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2019 Companies House Nummer: 10312979 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Healthcare Business Information Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2023 Companies House Nummer: 09857065 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Interface Clinical Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.07.2020 Companies House Nummer: 06076464 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Iqvia Investment Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2017 Companies House Nummer: 10586169 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag LH Perspectives LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2022 Companies House Nummer: 07032641 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Linguamatics Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2019 Companies House Nummer: 04248841 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Pharmaspectra Topco LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Companies House Nummer: 12125137 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB QH Research Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Companies House Nummer: 10026746 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Innovex UK LimitedInnovex House, Marlow Park, Marlow, Bucks, SL7 1TB