UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

MHL Holdco Limited

Adresse
886 The Crescent
Colchester Business Park
Colchester
CO4 9YQ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Februar 2023
Firmenbuch-Nummer 08585667 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)87100 - Pflegeheime
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Caring Homes Healthcare Group Limited
  • Myriad Group Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Myriad Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2020 Companies House Nummer: 12541403 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Consensus Group Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.04.2020 Löschung: 03.04.2020 Companies House Nummer: 12540112 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Jeffery, Paul Anthony Keith Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • gb-flag GB Myriad Healthcare Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.04.2020 Companies House Nummer: 09892549 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Cormack, Derek George Colchester Business Park, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2013 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish
    Griffin, Craig Colchester Business Park, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2014 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hill, Peter Martin Colchester Business Park, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2013 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jeffery, Paul Anthony Keith Colchester Business Park, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2013 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jeffrey, Helena Colchester Business Park, Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2013 Geburtsdatum: 08.1945 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Corstorphine, Iain Anderson Colchester Business Park, Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.05.2015 Löschung: 02.01.2024 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Fraser-Dale, Andrew David Colchester Business Park, Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2023 Löschung: 21.05.2024 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB CH (Benson) Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2020 Companies House Nummer: 12594995 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB CH Octopus (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2020 Companies House Nummer: 12447558 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Caring Homes (Berkshire) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09252206 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Caring Homes (Shropshire) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09878415 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Caring Homes (Standon) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09878540 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Caring Homes (TFP) Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Companies House Nummer: 09742920 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Caring Homes Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05587269 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Caring Homes Healthcare Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: 03764631 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • gb-flag GB Cheshire House Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04675237 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Aria Healthcare Group LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2022 Companies House Nummer: 06367517 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors