UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Proper Snacks LTD

Adresse
132 Townsend Drive
Attleborough Fields Industrial Estate
Nuneaton
CV11 6TJ
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 10317166 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 2. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Warp Snacks Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2021 Companies House Nummer: 13071913 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Balon, Adam Richard Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Kohn, Ryan Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 08.1983 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Piper Nominee Iv Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2016 Löschung: 17.08.2016 Companies House Nummer: 05491862 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Piper Pe Llp Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2016 Löschung: 26.02.2021 Companies House Nummer: Oc345898 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Stavrou, Cassandra Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2016 Löschung: 26.02.2021 Geburtsdatum: 01.1984 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Brittain, Alexander Shoji London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2024 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Halai, Ketan Attleborough Fields Industrial Estate, Nuneaton, England Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Stavrou, Cassandra Attleborough Fields Industrial Estate, Nuneaton, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Balon, Adam Richard 13 Bramley Road, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2016 Löschung: 26.02.2021 Beschäftigung: Partner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Schulze-Melander, Christoph Wolfgang Attleborough Fields Industrial Estate, Nuneaton, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2021 Löschung: 24.10.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wilkinson, Richard John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.04.2021 Löschung: 30.09.2021 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag Catapult Enterprises LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2016 Companies House Nummer: 07057804 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB PS (2016) LTD Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2016 Companies House Nummer: 10321599 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors