UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Inframe 051 Limited

Adresse
Units 8/9 Parsons Court Welbury Way
Aycliffe Business Park
Newton Aycliffe
DL5 6ZE
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 12836321 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • HSH Group Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    Allen, Stuart Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2024 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Walsh, James Status: Aktiv Eintragung: 08.05.2024 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Henley Living Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2020 Löschung: 19.11.2021 Companies House Nummer: 12827883 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Inframe Develop Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2021 Löschung: 08.05.2024 Companies House Nummer: 13560181 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Syon Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2020 Löschung: 22.11.2021 Companies House Nummer: 10406152 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Allen, Stuart James Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2020 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcconnell, Matthew Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Rolle: Secretary
    Walsh, James Cyril Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, Durham, England Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2021 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish