UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Hydratight Limited

Adresse
Unit 45
Colbourne Avenue Nelson Par
Cramlington
NE23 1WD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. März 2022
Firmenbuch-Nummer 03069889 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
Branche (ÖNACE)28290 - Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g.
43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Hydratight Sweeney Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Enerpac Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05452520 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Actuant Europe Holding Sasu, 6 Rue Du Quatre Septembre Immeuble Le Poversy, Issy Les Moulineaux, Paris, France, 92130 Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2013 Rolle: Director
    De Greef, Erik Martin Cramlington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2025 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Dutch
    Malik, Imran Khalid Cramlington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2025 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Actuant Europe Holding Sasu Immeuble Le Poversy, Issy Les Moulineaux, Paris, France, 92130 Status: Inaktiv Eintragung: 25.09.2013 Löschung: 20.12.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 502092125
    Chase-Hubbard, Kimberly Sue Wisconsin 53051, United States Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2022 Löschung: 24.01.2025 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Vice President & Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Jefferson, Philip Ashley Nelson Park, Cramlington, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2023 Löschung: 24.01.2025 Beschäftigung: President Of Emea Enerpac Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Maxted, Philip Roy Axcess 10 Business Park,, Bentley Road South Status: Inaktiv Eintragung: 03.06.2009 Löschung: 20.04.2012 Beschäftigung: Business Leader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    O'Connell, Paul James Nelson Park, Cramlington, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2021 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

    gb-flag GB D. L. Ricci LTD. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03399425 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag HTL Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2020 Companies House Nummer: 02868728 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hydratight Operations Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01385259 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Mirage Machines Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Companies House Nummer: 02788205 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more