UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Wellington Support LTD

Adresse
22-24 Harborough Road
Kingsthorpe
Northampton
NN3 3LL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
19. März 2019
FB Name Wellington Support Limited
FB Adresse Suite 22 The Globe Centre
Accrington
BB5 0RE
Firmenbuch-Nummer 07811657 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2022
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB National Care Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Companies House Nummer: 10080257 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Bustin, Janice Anne Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 06.1960 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Bustin, Richard James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 02.1975 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Allen, James Frank St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2019 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cleasby, Michael St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Quality Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lalani, Faisal St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Leake, Claire Jane St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: People Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lewis, Karen St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2019 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mawji, Jamil St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian
    Ranson, Michael St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2020 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Rowe-Bewick, David St James Square, Accrington, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British