UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

LSL Property Services PLC

Adresse
Newcastle House Albany Court
Newcastle Business Park
Newcastle Upon Tyne
NE4 7YB
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 05114014 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Broomco (3455) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Officers (11)

    Quelle: Companies House
    Appleton, Gabrielle Blossom Street, York, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Castleton, Adam Robert Blossom Street, York, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2015 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Collins, Adrian John Reginald Blossom Street, York, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Evans, Darrell Paul Blossom Street, York, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Fitzgerald, Sapna Bedi Blossom Street, York, England Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2005 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Secretary Nationalität: British
    Ghobrial, Sonya Blossom Street, York, England Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2022 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mack, Christopher James Blossom Street, York, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Stewart, David Newcastle Business Park, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2015 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Barral, David Barclay Blossom Street, York, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 26.02.2024 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Embley, Simon David Blossom Street, York, England Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2004 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Matthews, Roger John York, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2006 Löschung: 31.12.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag Advance Mortgage Funding Limited | Pink Home Loans Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02217569 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Direct Life Quote Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2021 Companies House Nummer: 10283300 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB E.Surv Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02264161 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lending Solutions Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05095079 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mortgage GYM Solutions LTD. Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2020 Companies House Nummer: 12460735 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB NEW Daffodil Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02045933 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Qualis Wealth Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2019 Companies House Nummer: 11784115 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reeds Rains Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02568254 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB ST Trinity Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07092652 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors