UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Allison Homes Limited

Adresse
Larkfleet House
Falcon Way
Southfields Business Park
Bourne
PE10 0FF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
FB Adresse Fleet House Cygnet Road
Bourne
PE7 8FD
Firmenbuch-Nummer 06235048 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Larkfleet Exclusives Limited
  • Larkfleet Land Company Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Allison Homes Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2021 Companies House Nummer: 10653289 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Larkfleet Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2017 Löschung: 14.06.2017 Companies House Nummer: 10653289 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Larkfleet Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.06.2017 Companies House Nummer: 09610856 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Larkfleet Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2017 Löschung: 30.09.2021 Companies House Nummer: 03520125 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Anderson, John Bruce Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Brown, Deborah Jane Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2014 Rolle: Secretary
    Jones, Darren Robert Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mabey, Glyn David Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Trinder, Ian Jens Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wallwork, Paul Antony Hewitt Hampton, Peterborough, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Allison Homes (Pinchbeck) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09885420 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Chapel Gate Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Companies House Nummer: 14083533 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB OLD School Court Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2021 Companies House Nummer: 06020854 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Oakham Heights Allotment Gardens Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2021 Companies House Nummer: 08273945 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Phase 10 Apartments 306-333 Buttercross Mews Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Companies House Nummer: 14208233 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Phase 9 Apartments 143-157 Farriers Mews (Oakham) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2022 Companies House Nummer: 14207509 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB RED Barn Park Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2021 Companies House Nummer: 05927550 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Oaks (Norwich) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Companies House Nummer: 14083618 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB The Orchards (Corby Glen) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2022 Companies House Nummer: 14083648 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Thorney Phase 2 Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2023 Companies House Nummer: 14866514 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control