UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Wateredge Hotel LTD

Adresse
Wateredge Bay
Ambleside
Cumbria
LA22 0EP
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
10. September 2022
FB Name Wateredge Hotel Limited
FB Adresse Inn Collection Group 3rd Floor, Q5
Newcastle Upon Tyne
NE12 8BS
Firmenbuch-Nummer 02962282 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 2. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Wateredge Hotel LTD | Wateredge INN
  • Wateredge Hotel LTD Wateredge INN
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Inn Collection Bidco 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Companies House Nummer: 13266496 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Cowap, Derek Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2016 Löschung: 15.04.2020 Geburtsdatum: 12.1941 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Cowap, Derek Mark Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2016 Löschung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Cowap, Derek Scott Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2016 Löschung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Cowap, Pamela Anne Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2016 Löschung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 04.1942 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Mcinerney, Louise Anne Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2016 Löschung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Bentley, Kate Quorum Business Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bernhoeft, Joseph Matthew Benton, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Donkin, Sean Lee Quorum Business Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2021 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Stewart, Louise Jane Quorum Business Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2022 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Property Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Edwards, Alexander Paul Newcastle Upon Tyne, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2021 Löschung: 27.10.2023 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British