UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Reward Finance Group Limited

Adresse
3rd Floor Central House
47 St Pauls Street
Leeds
LS1 2TE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Jänner 2023
FB Adresse 1st Floor 12 King Street
Leeds
LS1 2HL
Firmenbuch-Nummer 07385919 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Reward Investments Limited
  • Reward Capital Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Reward Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432546 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Truly Alternative Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.04.2017 Companies House Nummer: 09413124 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Cockerham, Emma Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Harrop, David Anthony Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2011 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Jones, David Alan Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2015 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Noble, Steven David Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Smith, Nicholas Stephen Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Stafford, Timothy Paul Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2015 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Risk Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Taylor, Andrew Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Rolle: Secretary
    Wright, Gemma Louise Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cockerham, Emma Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2020 Löschung: 27.03.2024 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

    gb-flag GB Reward Asset Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2024 Companies House Nummer: 13919550 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Reward Capital (A) Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Companies House Nummer: 13558424 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reward Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432492 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reward Invoice Finance (A) Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Companies House Nummer: 13558429 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Reward Invoice Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432479 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Reward Invoice Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432479 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reward SPV1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Companies House Nummer: 12373901 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors