UID-Suche.eu

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Reward Finance Group Limited

Adresse
Central House
47 St. Pauls Street
Leeds
LS1 2TE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. Dezember 2022
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
24. Jänner 2023
FB Adresse 1st Floor 12 King Street
Leeds
LS1 2HL
Firmenbuch-Nummer 07385919 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Reward Investments Limited
  • Reward Capital Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Reward Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432546 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Truly Alternative Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.04.2017 Companies House Nummer: 09413124 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Cockerham, Emma Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Geburtsdatum: 09.1988 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Harrop, David Anthony Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2011 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Jones, David Alan Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2015 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Noble, Steven David Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2020 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Smith, Nicholas Stephen Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Stafford, Timothy Paul Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2015 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Risk Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Taylor, Andrew Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Rolle: Secretary
    Wright, Gemma Louise Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cockerham, Emma Leeds, England Status: Inaktiv Eintragung: 28.10.2020 Löschung: 27.03.2024 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

    gb-flag GB Reward Asset Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2024 Companies House Nummer: 13919550 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Reward Capital (A) Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Companies House Nummer: 13558424 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reward Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432492 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reward Invoice Finance (A) Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Companies House Nummer: 13558429 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Reward Invoice Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432479 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Reward Invoice Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09432479 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Reward SPV1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Companies House Nummer: 12373901 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors